All announcements relating to the company CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, Londres, succursale de Genève published in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) or the e-official gazette of the Liechtenstein state government since 1994 are shown below. Additional background information and financial data for CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, Londres, succursale de Genève can be found under the additional menu items.

    SOGC: 114 / from 15.06.2017

    • Auflösung der Firma: GE Radiations CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CHE-112.801.390 (FOSC du 23.02.2015, p. 0/2005131). La succursale est radiée par suite de cessation de lexploitation. Journal no 10242 du 12.06.2017 03583095
  • SOGC: 36 / from 23.02.2015

    • Namensänderung, Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CHE-112.801.390 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Nouvelle raison sociale du siège principal: CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP. Par conséquent, la raison de commerce de la succursale devient: CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, Londres, succursale de Genève. Les pouvoirs de Russell Patrick James, Scott John Michael Elsworth et Fea James Henry sont radiés. Signature individuelle, limitée aux affaires de la succursale, a été conférée à Moncreiffe Mark Andrew, de Grande-Bretagne, à Genève, directeur de la succursale. Journal no 2766 du 18.02.2015 02005131
  • SOGC: 7 / from 11.01.2012

    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CH-660-0028006-1 (FOSC du 09.09.2010, p. 7/5805632). Holder James Douglas nest plus associé gérant; ses pouvoirs sont radiés. Procuration collective à deux, limitée à létablissement principal, a été conférée à Syed Mary Catriona Balfour, maintenant domiciliée à Londres, GB, et jusquici directrice de succursale; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Journal no 356 du 06.01.2012 06499226
  • SOGC: 175 / from 09.09.2010

    • Firmensitz geändert: GE Mutations CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CH-660-0028006-1 (FOSC du 15.02.2010, p. 10/5495694). Nouvelle adresse: rue du Prince 9-11, 1204 Genève. Journal no 14823 du 03.09.2010 05805632
  • SOGC: 31 / from 15.02.2010

    • Andere oder unbekannte Gründe: GE Mutations CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CH-660-0028006-1 (FOSC du 08.02.2010, p. 10/5483612). Linscription N° 1929 du 02.02.2010 est rectifiée en ce sens que le nom de famille dun associé-gérant est Scott et le prénom est John Michael Elsworth. Journal no 2371 du 09.02.2010 05495694
  • SOGC: 26 / from 08.02.2010

    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CH-660-0028006-1 (FOSC du 30.06.2009, p. 12/5102160). Signature individuelle a été conférée à lassocié Elswort Scott John Michael, nommé gérant, de Grande-Bretagne, à Londres, GB. Journal no 1929 du 02.02.2010 05483612
  • SOGC: 123 / from 30.06.2009

    • Andere oder unbekannte Gründe: GE Mutations CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CH-660-0028006-1, fourniture de services juridiques, etc. (FOSC du 10.06.2009, p. 9/5059914). Linscription 8022 du 04.06.2009 est rectifiée en ce sens que le nom de lassocié gérant Russel Patrick James sorthographie en réalité Russell Patrick James, et que Fea James Henry est en réalité directeur de la succursale. Journal no 9308 du 24.06.2009 05102160
  • SOGC: 109 / from 10.06.2009

    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, CH-660-0028006-1, fourniture de services juridiques pour une clientèle anglaise et étrangère (FOSC du 08.03.2006, p. 7/3277352). Suite à la modification du droit du registre du commerce et en application de lart. 114 al. 1 lit. f ORC, la radiation de lensemble des associés sans pouvoir de signature est requise. Par conséquent, linscription de Howell Grant, Adlard Helen Elizabeth, Anticoni Sarah Therese, Armstrong Nicholas David, Bennett Michael Phillip, Berry David Harold, Blower Robert Henry, Bradshaw Michael Thomas, Brothwood Ian James, Bynde Robin William, Carter Stephen Leonard, Castle Jacquetta Louise, Clason Andrew Mckinlay, Code Stephanie, Coles Peter Arthur Edward, Collins Richard Andrew, Cover Michael David, Cozens Susan Jane, Critchley Paul Anthony, Crowe Amanda Louise, Davidson David Murray, Davies Simon Alan, Drew Catherine Ann, Duncan George Lindsay, Elliott Peter Muir, Elson Duncan William, Fletcher John Holisey, Fordyce Rory Peter Heddle, Galloway Timothy William, Gearon Patrick David, Gilbert Simon Adrian, Glynn Philippa, Gordon Keir Watson, Green David James Shore, Harriman William Paul, Hey Stewart Radcliffe, Higgins Sarah Dorothy, Highmore Robert Peter, Hopewell Clive Matthew, Horner David Jeremy, Hurley Nicholas Simon, Jenkins Timothy Paul, Jordan Geoffrey William, Keepin Alexander Ian, Lall Tarlochan, Lamont Duncan Michael, Lanni Vincenzo, Lecchi Emanuela Amelia Angela, Levaggi Peter, Long David Eric, Longrigg William Fallowfield, Marriott Jack, Marriott Suzanne Jane, Mayer Adrian George Alan, Moncrieffe Mark Andrew Charles, Morton Nigel John, Norton Richard William Fisher, Owers Joanne, Page Christopher John, Pallister Stephen, Palmer Brian Martin, Partridge Robert Anthony, Perry William John, Pidgeon Nicholas John, Pierce Jennifer Josephine, Pierce Roger Thomas William, Povey Lynn Joan, Powel Keith Martyn, Powner Michael Gerard, Reissner David Henry, Rundall Francis Richard Seton, Saiban Jason Asnam, Savage David James, Scandrett Peter David, Scott John Michael Elsworth, Shelton Erica Augusta, Slatter Andrew Kenneth, Soloman Amanda, Sparks Geoffrey James, Stevens Amanda Joan, Sykes John Richard Hindmarsh, Tombolis Glafkos, Tyson Margaret Ann, Vallance Richard Anthony, Weber Kristen Mark et West Antione Richard en tant quassociés est radiée. Les pouvoirs de Watt Lawrence Johnstone sont radiés. La directrice de succursale Syed Mary Catriona Balfour, jusquici associée, continue à signer individuellement, pour les affaires de la succursale. Signature individuelle a été conférée aux associés Holder James Douglas et Russel Patrick James, nommés gérants. Signature individuelle, limitée aux affaires de la succursale a été conférée à Fea James Henry, de Grande-Bretagne, à Genève, directeur. Journal no 8022 du 04.06.2009 05059914
  • SOGC: 47 / from 08.03.2006

    • Gründung der Firma, Namensänderung, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Nouvelles inscriptions CHARLES RUSSELL LLP, Londres, succursale de Genève, à Genève, rue du Rhône 14, CH-660-0028006-1. Succursale de CHARLES RUSSEL LLP, limited liability partnership, à Londres, GBR, inscrite auprès du Registrar of Companies for England and Wales le 24.02.2005 sous le numéro OC 311850. Statuts du 24.02.2005. But: fourniture de services juridiques pour une clientèle anglaise et étrangère. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Associés: Syed Mary Catriona Balfour, de Grande-Bretagne, à Genève, et Adlard Helen Elizabeth, Armstrong Nicholas David, Watt Lawrence Johnstone,gérant, Cooke Ian James, Anticoni Sarah Therese, Bennett Michael Phillip, Berry David Harold, Blower Robert Henry, Bradshaw Michael Thomas, Brothwood Ian James, Bynde Robin William, Carter Stephen Leonard, Castle Jacquetta Louise, Clason Andrew Mckinlay, Code Stéphanie, Coles Peter Arthur Edward, Collins Richard Andrew, Cover Michael David, Cozens Susan Jane, Critchley Paul Anthony, Crow Amanda Louise, Davidson David Murray, Davis Simon Alan, Drew Catherine Ann, Duncan George Lindsay, Elliott Peter Muir, Elson Duncan William, Fletcher John Holisey, Fordyce Rory Peter Heddle, Galloway Timothy William, Gearon Patrick David, Gilbert Simon Adrian, Glynn Philippa, Gordon Keir Watson, Green David James Shore, Harriman William Paul, Hey Stewart Radcliffe, Higgins Sarah Dorothy, Highmore Robert Peter, Holder James Douglas, Hopewell Clive Matthew, Horner David Jeremy, Howell Grant, gérant, Hurley Nicholas Simon, Jenkin Timothy Paul, Jordan Geoffrey William, Keepin Alexander Ian, Lall Tarlochan, Lamont Duncan Michael, Lanni Vincenzo, Lecchi Emanuela Amelia Angela, Levaggi Peter, Long David Eric, Longrigg William Fallowfield, Marriott Jack, Marriott Suzanne Jane, Mayer Adrian George Alan, Moncrieffe Mark Andrew Charles, Morton Nigel John, Norton Richard William Fisher, Owers Joanne, Page Christopher John, Pallister Stephen, Palmer Brian Martin, Partridge Robert Anthony, Peerles Bartholomey Guy, Perry William John, Pidgeon Nicholas John, Pierce Roger Thomas William, Pierce Jennifer Josephine, Povey Lynn Joan, Powel Keith Martyn, Powner Michael Gerard, Reissner David Henry, Rundall Francis Richard Seton, Russel Patrick James, Saiban Jason Asnam, Savage David James, Scandrett Peter David, Scott John Michael Elsworth, Shelton Erica Augusta, Slatter Andrew Kenneth, Soloman Amanda, Sparks Geoffrey James, Stevens Amanda Joan, Sykes John Richard Hindmarsh, Tombolis Glafkos, Tyson Margaret Ann, Vallance Richard Anthony, Weber Kristen Mark, West Antione Richard, tous de Grande-Bretagne, à Londres, GB. Signature individuelle de lassocié-gérant Watt Laurence Johnstone. Signature individuelle limitée aux affaires de la succursale de lassociée Syed Mary Catriona Balfour, directrice. Procuration individuelle limitée aux affaires de la succursale des associés Cooke Ian James et Peerless Bartholomey Guy. Journal no 2933 du 02.03.2006 03277352
Advertisement
Advertisement